Nuova ricerca
1-20 di 1.076.874
Non è disponibile perché è attivo un filtro del luogo, della data o dell’immagine

Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni

  1. Informazioni sul documento.
    Nome
    Jennie M Lying
    Residenza
    1910 Missoula, Montana, USA (Stati Uniti)
  2. Informazioni sul documento.
    Nome
    Paschal Lying
    Decesso
  3. Informazioni sul documento.
    Nome
    Ann Lying
    Nascita
    Decesso
    xx xxx

    C’è altro da vedere.

    Fai clic per iscriverti adesso.
    1648
  4. Informazioni sul documento.
    Nome
    Richard Talbot, PC, 1st Duke of Tyrconnell, Groom of the Bedchamber to Duke of York (King James II), Royalist, "Lying Dick Talbot"
    Nascita
    Decesso
  5. Informazioni sul documento.
    Nome
    Richard Talbot, PC, 1st Duke of Tyrconnell, Groom of the Bedchamber to Duke of York (King James II), Royalist, "Lying Dick Talbot"
    Nascita
    Decesso
  6. Informazioni sul documento.
    Nome
    Jessie May Lying
    Nascita
    Decesso
    x xxx

    C’è altro da vedere.

    Fai clic per iscriverti adesso.
    1935
  7. Informazioni sul documento.
    Nome
    Karl Bertil Lying
    Nascita
    Decesso
  8. Informazioni sul documento.
    Nome
    Jonathan (m.Gibbons/Davee) Tyng / Ting / Lying / Thing
    Nascita
    Decesso
  9. Informazioni sul documento.
    Nome
    Anne Hannah Lying
    Nascita
  10. Informazioni sul documento.
    Nome
    Alice (Lying?)
    Nascita
    Decesso
    1651
  11. Informazioni sul documento.
    Nome
    Edward Messenger -Messinger-Lived in the Windosr Settlement c 1650, owned land in Bloomfield Connecticut-He was once sentenced By The Court To Be Whipped For His Merciless Treatment of A Servant & Then Lying To Lessen His Fault
    Nascita
    Decesso
  12. Informazioni sul documento.
    Nome
    Samuel Laing
    Nascita
    Decesso
    1897
  13. Informazioni sul documento.
    Nome
    W A Laing
    Residenza
    1918 USA (Stati Uniti)
  14. Informazioni sul documento.
    Nome
    Walter A Laing
    Residenza
    1918 River Forest, Illinois, USA (Stati Uniti)
  15. Informazioni sul documento.
    Nome
    Sarah E Ludlow
    Residenza
    1851-1900 Rahway, Union, New Jersey, USA (Stati Uniti)
  16. Informazioni sul documento.
    Nome
    Sir George Laing
    Nascita
    Decesso
    1956
  17. Regno Unito, Fotografie e stampe storiche, 1704-1989
    (2 immagini in totale nel pacchetto)
    Immagini
    Informazioni sul documento.
    Nome
    Dr T N Ling
  18. Regno Unito, Fotografie e stampe storiche, 1704-1989
    (2 immagini in totale nel pacchetto)
    Immagini
    Informazioni sul documento.
    Nome
    Dr T N Ling
  19. Regno Unito, Fotografie e stampe storiche, 1704-1989
    (2 immagini in totale nel pacchetto)
    Immagini
    Informazioni sul documento.
    Nome
    Dr T M Ling
  20. Regno Unito, Fotografie e stampe storiche, 1704-1989
    (2 immagini in totale nel pacchetto)
    Immagini
    Informazioni sul documento.
    Nome
    Dr T M Ling
  1. Decesso
    xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  2. Nascita
    xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
    Decesso
    xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  3. Residenza
    1918
    River Forest, Illinois, USA (Stati Uniti)
  4. Residenza
    1851-1900
    Rahway, Union, New Jersey, USA (Stati Uniti)
1-20 di 1.076.874 risultati
per pagina

Tasti di scelta rapida

  • Alt + nNuove
  • Alt + rOttimizza
  • Alt + pAnteprima documento
  • Alt + ]Risultato successivo
  • Alt + [Risultato precedente